Krajowy Rejestr historycznych miejsc ofert w Hrabstwo Moore, Karolina Północna - National Register of Historic Places listings in Moore County, North Carolina

Wszystkie współrzędne na mapie za pomocą: OpenStreetMap 
Pobierz współrzędne jako: KML  ·  GPX
North Carolina Mapa Podświetlanie Moore County.PNG

Lista ta zawiera właściwości i dzielnice wymienione na National Register of Historic Places w Moore County w Północnej Karolinie . Kliknij „mapa wszystkich współrzędnych” link do prawej strony, aby wyświetlić mapę Google wszystkich właściwości i powiatów z współrzędne geograficzne w poniższej tabeli.

Aktualne ofert

Ten National Park Service lista jest kompletna przez NPS ostatnich ofert opublikowanych 30 listopada 2018.
Imię w Rejestrze Obraz Data wymienione Lokalizacja Miasto czy miasteczko Opis
1 Aberdeen Historic District
Aberdeen Historic District
28 czerwca 1989
( # 89000663 )
Grubsza ograniczony Klon Ave., Bethesda Ave., Campbell St. Main St., ul, South Pine ul, topola ul
35 ° 07'53 "N 79 ° 25'29" W  /  35.131389 ° ° W N 79.424722 / 35.131389; -79,424722 ( Aberdeen Historic District )
Aberdeen
2 Alston House
Alston House
26 lutego 1970
( # 70000462 )
SE z Glendon na SR 1624
35 ° 28'00 "N 79 ° 23'02" W  /  35,466797 ° W ° N 79.383867 / 35.466797; -79,383867 ( Alston House )
Glendon
3 Bethesda Presbyterian Church
Bethesda Presbyterian Church
22 lipca 1979
( # 79003345 )
NC 5
35 ° 07'52 "N 79 ° 24'45" W  /  35,131111 ° W ° N 79,4125 / 35.131111; -79,4125 ( Bethesda Presbyterian Church )
Aberdeen
4 JC Czarny Dom
JC Czarny Dom
08 lipca 1999
( # 99000811 )
106 McNeill Ul
35 ° 20'44 "N 79 ° 24'55" W  /  35,345556 79,415278 ° N ° W / 35.345556; -79,415278 ( JC Czarny Dom )
Carthage
5 Czarno-Cole Dom 18 września 1978
( # 78001967 )
NW Eastwood
35 ° 16'03 "N 79 ° 29'16" W  /  35,2675 ° W ° N 79,487778 / 35,2675; -79,487778 ( Czarno-Cole Dom )
Eastwood
6 Daniel Blue House 21 lipca 1983
( # 83001897 )
SR 1836
35 ° 16'55 "N 79 ° 25'32" W  /  35,281944 79,425556 ° N ° W / 35.281944; -79,425556 ( Daniel Blue House )
Carthage
7 John Blue House 29 lipca 1982
( # 82003488 )
200 ul niebieski
35 ° 07'50 "N 79 ° 25'22" W  /  35,130556 79,422778 ° N ° W / 35.130556; -79,422778 ( John Blue House )
Aberdeen
8 Malcolm Niebieski rolnicze
Malcolm Niebieski rolnicze
01 czerwca 1982
( # 82003489 )
Bethesda Rd. Ernest L. Ives Dr
35 ° 08'08 "N 79 ° 24'38" W  /  35,135556 79,410556 ° N ° W / 35.135556; -79,410556 ( Malcolm Niebieski Farm )
Aberdeen
9 James Boyd Dom
James Boyd Dom
Maj 12, 1977
( # 77001005 )
Ridge Rd. i Connecticut Ave.
35 ° 10'14 "N 79 ° 23'00" W  /  35,170556 79,383333 ° N ° W / 35.170556; -79,383333 ( James Boyd Dom )
Southern Pines
10 Bruce-Dowd-Kennedy House 29 września 1980
( # 80002888 )
Monroe i Rockingham św.
35 ° 20'34 "N 79 ° 24'48" W  /  35,342778 79,413333 ° N ° W / 35.342778; -79,413333 ( Bruce-Dowd-Kennedy House )
Carthage
11 James Bryant Dom 15 kwietnia 1982
( # 82003490 )
Na SR 1210
35 ° 19'07 "N 79 ° 32'41" W  /  35,318611 79,544722 ° N ° W / 35.318611; -79,544722 ( James Bryant Dom )
Harris Crossroads
12 Cameron Historic District 17 marca 1983
( # 83001898 )
Carthage St. z US 1, Seaboard RR Tory
35 ° 19'36 "N 79 ° 15'28" W  /  35,326667 79,257778 ° N ° W / 35.326667; -79,257778 ( Cameron Historic District )
Cameron
13 Carthage Historic District
Carthage Historic District
19 marca 1992
( # 92000182 )
Z grubsza, McReynolds St. między Barrett St. i Glendons Rd. oraz części Barrett, promień, Pinecrest Brooklyn św.
35 ° 21'04 "N 79 ° 25'23" W  /  35,351111 79,423056 ° N ° W / 35.351111; -79,423056 ( Carthage Historic District )
Carthage
14 Firleigh Farms Maj 19, 2014
( # 14000229 )
252 Fir Leigh Rd.
35 ° 10'16 "N 79 ° 21'17" W  /  35,1710 79,3546 ° N ° W / 35,1710; -79,3546 ( Firleigh Farms )
Southern Pines
15 Gordon Payne Site (31MR15) 24 września 1986
( # 86001954 )
adres Ograniczone
High Falls
16 Jugtown Pottery 12 listopada 1999
( # 99001284 )
330 Jugtown Rd.
35 ° 30'27 "N 79 ° 39'06" W  /  35,5075 ° W ° N 79,651667 / 35,5075; -79,651667 ( Jugtown ceramika )
Seagrove
17 Alexander Kelly Dom
Alexander Kelly Dom
02 maja 2002
( # 02000438 )
NC 1640, 0,3 mil na południowy wschód od Jct. NC 1666
35 ° 22'34 "N 79 ° 26'46" W  /  35,376111 79,446111 ° N ° W / 35.376111; -79,446111 ( Alexander Kelly Dom )
Carthage
18 Lakeview Historic District Maj 18, 2000
( # 00000513 )
Obóz Easter Rd., Crystal Lake Dr Holly Rd., Matthews Rd., A McFayden Ln.
35 ° 14'25 "N 79 ° 18'41" W  /  35,240278 79,311389 ° N ° W / 35.240278; -79,311389 ( Lakeview Historic District )
Widok na jezioro
19 Leslie Taylor-Dom 17 stycznia 2008
( # 07001407 )
270 Carthage Rd.
35 ° 15'26 "N 79 ° 17'47" W  /  35,257233 ° W ° N 79,2963 / 35.257233; -79,2963 ( Leslie Taylor-Dom )
Vass
20 Lincoln Park Szkoła 27 lutego 1997
( # 97000167 )
1272 S. porzeczki Ul
35 ° 05'06 "N 79 ° 28'25" W  /  35,085 ° N ° W 79,473611 / 35,085; -79,473611 ( Lincoln Park Szkoła )
Pinebluff
21 Lloyd-Howe Dom
Lloyd-Howe Dom
08 września 1983
( # 83001899 )
SW z Pinehurst
35 ° 11'15 "N 79 ° 29'38" W  /  35,1875 ° W ° N 79,493889 / 35,1875; -79,493889 ( Lloyd-Howe Dom )
Pinehurst
22 McLeod rodziny wiejskiej Complex 20 grudnia 1984
( # 84000561 )
.4 mil zachód amerykańskich 1
35 ° 04'33 "N 79 ° 30'06" W  /  35,075833 79,501667 ° N ° W / 35.075833; -79,501667 ( McLeod rodziny wiejskiej Complex )
Pinebluff
23 Courthouse Hrabstwo Moore
Courthouse Hrabstwo Moore
Maj 10, 1979
( # 79001738 )
Ray, Dowd, Monroe, a Sanders św. Koło
35 ° 20'44 "N 79 ° 25'00" W  /  35,345556 79,416667 ° N ° W / 35.345556; -79,416667 ( Courthouse Moore County )
Carthage
24 Grunty Hrabstwo Moore polować i mila-away Farms 9 września 2013
( # 13000700 )
1745 N. maja Ul
35 ° 11'14 "N 79 ° 22'00" W  /  35,187094 79,366683 ° N ° W / 35.187094; -79,366683 ( Lands Hrabstwo Moore polować i mila-Away Farms )
Southern Pines
25 John Phillips Dom Evander 06 października 2000
( # 00001184 )
NC 24/27, 0,3 mil poza Cameron
35 ° 19'47 "N 79 ° 15'45" W  /  35,329722 ° W ° N 79,2625 / 35.329722; -79,2625 ( John Phillips Evander Dom )
Cameron
26 Pinehurst Historic District
Pinehurst Historic District
14 sierpnia 1973
( # 73001361 )
Grubsza ograniczona Norfolk & Southern ścieżek RR McLean Rd. NC 5
35 ° 11'41 "N 79 ° 28'11" W  /  35,194722 79,469722 ° N ° W / 35.194722; -79,469722 ( Pinehurst Historic District )
Pinehurst
27 Pinehurst Race Track
Pinehurst Race Track
27 listopada 1992
( # 92001628 )
Jct. od Morgantown Rd. NC 5 rogu SE
35 ° 10'54 "N 79 ° 27'59" W  /  35,181667 79,466389 ° N ° W / 35.181667; -79,466389 ( Race Pinehurst Tor )
Pinehurst
28 Shaw House
Shaw House
17 czerwca 1993
( # 93000542 )
780 SW. Szerokie Ul
35 ° 10'05 "N 79 ° 24'06" W  /  35,168056 79,401667 ° N ° W / 35.168056; -79,401667 ( Shaw House )
Southern Pines
29 Southern Pines Historic District
Southern Pines Historic District
27 grudnia 1991
( # 91001875 )
Ograniczona przez Saylor St., New Jersey Ave., Illinois Ave. i Massachusetts Ave. Wew.
35 ° 10'10 "N 79 ° 23'17" W  /  35,169444 79,388056 ° N ° W / 35.169444; -79,388056 ( Southern Pines Historic District )
Southern Pines

Zobacz też

Referencje